Podobne dokumenty
Raport bieżący nr 13/2016 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016 r.

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000;

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

RESOLUTION NO... OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA. dated 13 June 2008

At the request of shareholder OGM s Agenda was amended by change of p. 9j) and addition of p.9k)

Uchwała nr 04/05/2017. Resolution no 04/05/2017. Rady Nadzorczej Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 maja 2017 roku

RB 8/2014 Extraordinary General Meeting of BOŚ S.A. resolutions of 13 March released 13 March 2014

No. 2/2017. Poznań, 30 czerwca 2017 r.

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/

31 December 2017 reflecting other total net income of PLN 5,249,000;

RB 40/2016. Na wniosek akcjonariusza zmieniony został porządek obrad ZWZA poprzez zmianę brzmienia pkt 9j) oraz poprzez dodanie pkt 9k).

Current Report No. 14/2012 Wysogotowo, March 16th 2012

26 września 2019 r. 26 September Accor S.A. 82 Rue Henri Farman, Issy-les-Moulineaux Francja. Accor S.A. 82 Rue Henri Farman, France

Beata Maciąg Board Member Grzegorz Latała - Board Member

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013. Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A.

Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanemu na dzień 28 czerwca 2017 r.

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

Current Report no. 27/2019

Pruszków, 15 marca 2019 r. / Pruszków, March 15, 2019

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 32/2013

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. ( Spółka ) z dnia 21 czerwca 2017 r. KSH Akcje Program

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Resolution No.. of the Ordinary General Meeting of the Company Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. dated 30 th May 2014

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Warszawa, dnia 4 marca 2019 r. Warsaw, March 4 th, Oświadczenie Rady Nadzorczej. Statement of the Supervisory Board

The Extraordinary General Meeting of Shareholders hereby adopts the agenda in the following

Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanemu na dzień 17 maja 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF

Current Report no. 35/2019

d) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANNOUNCEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING CONVENING

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ

FORMULARZ. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona S.A. z siedzibą w Warszawie

Current Report 16/2018

Draft resolutions for the Extraordinary General Meeting of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna convened for 21 April 2015

Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A.

Warszawa, dnia 5 maja 2014 r.

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 14/2015 Data sporządzenia: 2015%05%15

Draft resolutions for the Extraordinary General Meeting of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna convened for 2 May 2016

Jason Clarke. date of its adoption. In favour: 7 Against: 0 Abstained: 0. Za: 7 Przeciw: 0 Wstrzymujący się: 0. Dr Michael F.

DRAFT RESOLUTIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GETIN NOBLE BANK S.A.

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

FORMULARZ. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona S.A. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona S.A. z siedzibą w Warszawie

1. OTWARCIE OBRAD ORAZ OGŁOSZENIA; WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ORAZ PROTOKOLANTA OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

PRELIMINARY RESOLUTIONS

CARPATHIA CAPITAL S.A. Krasińskiego 16, Poznań, Poland T:

Kodeks spółek handlowych

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

In favor: 7 Against: 0 Abstained: 0

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.

Raport bieżący: 44/2018 Data: g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R.

ATLANTIS SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ATLANTIS SE PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

POWER OF ATTORNEY TO PARTICIPATE IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA. HELD ON SEPTEMBER 16, 2014

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Draft Resolutions of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Convened for April 28th 2008

SYMBIO POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za okres od do roku

Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Uchwała nr 595/7/2011 Resolution No. 595/7/2011

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

Regulamin Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń dostępny jest na stronach internetowych Banku

Current Report 49/2017

Raport bieżący nr 16 / 2009

Dokumentacja przedstawiana Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanemu na dzień 21 października 2015 r.

No. 17/2018. Poznań, 26 July 2018 r.

2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, c) Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Echo Investment S.A. i jej Grupy za 2018 rok

POLITYKA I PROCEDURA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ ORAZ POLITYKA ŚWIADCZENIA DODATKOWYCH USŁUG PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ LUB PODMIOT POWIĄZANY Z TĄ FIRMĄ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 27/2013. Temat The Annual General Meeting of Shareholders - Convening Notice

April 26, :00 PM

Resolution No... of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna, dated...

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWER OF ATTORNEY TO PARTICIPATE IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA. HELD ON DECEMBER 21, 2015

Current Report 23/2019

Kodeks spółek handlowych

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANNOUNCEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING CONVENING

ANNOUNCEMENT OF THE MANAGEMENT BOARD OF CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA OF THE CONVENING OF THE ORDINARY GENERAL MEETING

25 kwietnia 2018 r. godz. 19:30

CARPATHIA CAPITAL S.A. Krasińskiego 16, Poznań T: E:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: Temat Shareholder's Notification

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Wykaz Raportów. Raporty bieżące. Tytuł raportu. Data przekazania. raportu

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

The date, time, and location of the OGM as well as the detailed agenda


Raport bieżący nr 16 / 2017

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

April 21, :00 PM St. Casimir s Parish Hall 154 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

MERGER PLAN. for Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. and Rabobank Polska S.A.

1. 13 section 1 of the Articles of Association shall read as follows: ust. 1 Statutu otrzymuje nast puj ce brzmienie:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH: MERGER PLAN FOR CAPITAL COMPANIES: INOUTIC/ DECEUNINCK SP. Z O.O. i PROFIL SYSTEM SP. Z O.O.

Transkrypt:

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened for 23rd May 2007 Contents: The Board of Directors of PBG SA hereby publishes resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders of PBG S.A. convened for 23rd May 2007: Resolution no. 1 on the election of Chairperson of the General Meeting of Shareholders Pursuant to Article 409 item 1 of the Code of Commercial Companies the General Meeting of Shareholders of PBG S.A. with its registered office in Wysogotowo hereby appoints Mr. Andrzej Wliczyński as the Chairperson of the General Meeting of Shareholders. Resolution no. 2 on the election of the Voting Committee Under Art. 15 of the By-laws of the General Meeting of Shareholders, the General Meeting of Shareholders of PBG S.A. seated in Wysogotowo hereby elects the following members of the Voting Committee: - Ms. Florczuk Katarzyna - Mr. Szczepaniak Paweł - Mr. Tomasz Tomczak Resolution no. 3 1/8

on the approval of the financial statements for year 2006 and the Board's report on the Company s business in 2006 Pursuant to Art. 28 item 1 of the Articles of Association and Art. 395 item 2.1 of the hereby approves the financial statement for year 2006 and the Board s report on the Company s business in 2006. Resolution no. 4 on the distribution of profit Pursuant to Art. 28 item 3 of the Articles of Association and Art. 395 item 2.2 of the Code of Commercial Companies, the General Meeting of Shareholders hereby decides not to distribute the net profit as demonstrated in the Company s financial statements for 2006 and designate from the said profit PLN 2,000,000.00 (two million zlotys) to the company social benefits fund, while the remaining amount designate for reserve capital. Resolution no. 5 on discharging Mr. Jerzy Wiśniewski for due performance of his duties Pursuant Article 28 item 2 of the Articles of Association and Art. 395 item 2.3 of the hereby decides to discharge Mr. Jerzy Wiśniewski, President of the Board of Directors, for due performance of his duties in 2006. Resolution no. 6 on discharging Ms. Małgorzata Wiśniewska for due performance of her duties 2/8

hereby decides to discharge Ms. Małgorzata Wiśniewska, Vice President of the Board of Directors, for due performance of her duties in 2006. Resolution no. 7 on discharging Mr. Tomasz Woroch for due performance of his duties hereby decides to discharge Mr. Tomasz Woroch, Vice President of the Board of Directors, for due performance of his duties in 2006. Resolution no. 8 on discharging Mr. Przemysław Szkudlarczyk for due performance of his duties hereby decides to discharge Mr Przemysław Szkudlarczyk, Vice President of the Board of Directors, for due performance of his duties in 2006. Resolution no. 9 on discharging Mr. Tomasz Tomczak for due performance of his duties hereby decides to discharge Mr. Tomasz Tomczak, Vice President of the Board of Directors, for due performance of his duties in 2006. 3/8

Resolution no. 10 on discharging Mr. Mariusz Łożyński for due performance of his duties hereby decides to discharge Mr Mariusz Łożyński, Board member, for due performance of his duties in 2006. Resolution no. 11 on discharging Mr. Maciej Bednarkiewicz for due performance of his duties hereby decides to discharge Mr Maciej Bednarkiewicz, Chairman of the Supervisory Board, for due performance of his duties in 2006. Resolution no. 12 on discharging Mr. Wiesław Lindner for due performance of his duties hereby decides to discharge Mr Wiesław Lindner, Vice Chairman of the Supervisory Board, for due performance of his duties in 2006. Resolution no. 13 on discharging Mr. Jacek Krzyżaniak for due performance of his duties hereby decides to discharge Mr Jacek Krzyżaniak, Member and Secretary of the Supervisory Board, for due performance of his duties in 2006. 4/8

Resolution no. 14 on discharging Mr. Dariusz Sarnowski for due performance of his duties hereby decides to discharge Mr Dariusz Sarnowski, member of the Supervisory Board, for due performance of his duties in 2006. Resolution no. 15 on discharging Mr. Adam Strzelecki for due performance of his duties hereby decides to discharge Mr Adam Strzelecki, member of the Supervisory Board, for due performance of his duties in 2006. Resolution no. 16 on discharging Mr. Mirosław Dobrut for due performance of his duties hereby decides to discharge Mr Mirosław Dobrut, member of the Supervisory Board, for due performance of his duties in 2006. Resolution no. 17 on discharging Ms. Małgorzata Wiśniewska for due performance of her duties 5/8

hereby decides to discharge Ms Małgorzata Wiśniewska, Member of the Supervisory Board, for due performance of her duties in 2006. Resolution no. 18 on the establishment of the number of Supervisory Board Members Pursuant to Art. 29 item 2 the Articles of Association the General Meeting of Shareholders of PBG S.A. hereby decides that the Supervisory Board of the third term shall be composed of 8 (say: eight) members. Resolution no. 19 on appointing Supervisory Board Members Pursuant to Art. 28 item 8 of the Company s Articles of Association, the Annual General Meeting of Shareholders of PBG S.A. hereby appoints the following members of the Supervisory Board of PBG S.A.: - Bednarkiewicz Maciej - Dobrut Mirosław - Krzyżaniak Jacek - Kseń Jacek - Lindner Wiesław - Sarnowski Dariusz - Strzelecki Adam - Wiśniewska Małgorzata Resolution no. 20 on amendments to the Company s Articles of Association 6/8

Pursuant to provisions of Article 430 of the Code of Commercial Companies, the General Meeting of Shareholders of PBG S.A. hereby amends the Articles of Associations as follows: 1.Art. 10 item 1 shall read: 4,500,000 series A registered shares, 1,200,000 series A bearer shares. 2.Art. 11 item 2 shall read: The Company founders named in Art. 8 of the Company s Articles of Association holding series A shares shall have the pre-emptive right to acquire series A shares. 3.Art. 14 item 1 shall read: Each series A registered share carries 2 votes. 4.Art. 14 item 3 shall read: Preference as to vote expires upon the disposal of series A shares, unless the purchase is made by the hitherto shareholder who exercises the pre-emptive right mentioned in Art. 11 item 2 of the Articles of Association (in such case, the preference remains in effect). Preference as to vote also remains in force, when series A shares disposed by the hitherto shareholder who exercises the pre-emptive right mentioned in Art. 11 Item 2 of the Articles of Association, will be acquired by an entity, in which the abovementioned party disposing of series A shares is exclusively competent to manage the affaires of the said entity or a right to appoint the bodies of this entity and their members (particularly, the Board of Directors). Resolution no. 21 on authorising the Supervisory Board to prepare a consolidated text of the Company s Articles of Association Pursuant to provisions of Article 430 item 5 of the Code of Commercial Companies, the General Meeting of Shareholders of PBG S.A. hereby authorises the Supervisory Board to prepare a consolidated text of the Company s Articles of Association with the amendments adopted today by the Annual General Meeting of Shareholders. INFORMATION ON OBJECTIONS AGAINST THE RESOLUTIONS SUBJECT TO VOTING: After voting through Resolution no. 20, representative of ING Nationale Nederlanden Polska OFE, Mr. Paweł Szczepański objected to the said resolution. 7/8

Legal basis: Art. 39 item 1.5 of the Regulation of 19th October 2005 on current and interim information provided by issuers of securities. Signature of the authorised person: Magdalena Eckert-Boruta 8/8