|
|
- Gabriela Nowak
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened for 23rd May 2007 Contents: The Board of Directors of PBG SA hereby publishes resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders of PBG S.A. convened for 23rd May 2007: Resolution no. 1 on the election of Chairperson of the General Meeting of Shareholders Pursuant to Article 409 item 1 of the Code of Commercial Companies the General Meeting of Shareholders of PBG S.A. with its registered office in Wysogotowo hereby appoints Mr. Andrzej Wliczyński as the Chairperson of the General Meeting of Shareholders. Resolution no. 2 on the election of the Voting Committee Under Art. 15 of the By-laws of the General Meeting of Shareholders, the General Meeting of Shareholders of PBG S.A. seated in Wysogotowo hereby elects the following members of the Voting Committee: - Ms. Florczuk Katarzyna - Mr. Szczepaniak Paweł - Mr. Tomasz Tomczak Resolution no. 3 1/8
2 on the approval of the financial statements for year 2006 and the Board's report on the Company s business in 2006 Pursuant to Art. 28 item 1 of the Articles of Association and Art. 395 item 2.1 of the hereby approves the financial statement for year 2006 and the Board s report on the Company s business in Resolution no. 4 on the distribution of profit Pursuant to Art. 28 item 3 of the Articles of Association and Art. 395 item 2.2 of the Code of Commercial Companies, the General Meeting of Shareholders hereby decides not to distribute the net profit as demonstrated in the Company s financial statements for 2006 and designate from the said profit PLN 2,000, (two million zlotys) to the company social benefits fund, while the remaining amount designate for reserve capital. Resolution no. 5 on discharging Mr. Jerzy Wiśniewski for due performance of his duties Pursuant Article 28 item 2 of the Articles of Association and Art. 395 item 2.3 of the hereby decides to discharge Mr. Jerzy Wiśniewski, President of the Board of Directors, for due performance of his duties in Resolution no. 6 on discharging Ms. Małgorzata Wiśniewska for due performance of her duties 2/8
3 hereby decides to discharge Ms. Małgorzata Wiśniewska, Vice President of the Board of Directors, for due performance of her duties in Resolution no. 7 on discharging Mr. Tomasz Woroch for due performance of his duties hereby decides to discharge Mr. Tomasz Woroch, Vice President of the Board of Directors, for due performance of his duties in Resolution no. 8 on discharging Mr. Przemysław Szkudlarczyk for due performance of his duties hereby decides to discharge Mr Przemysław Szkudlarczyk, Vice President of the Board of Directors, for due performance of his duties in Resolution no. 9 on discharging Mr. Tomasz Tomczak for due performance of his duties hereby decides to discharge Mr. Tomasz Tomczak, Vice President of the Board of Directors, for due performance of his duties in /8
4 Resolution no. 10 on discharging Mr. Mariusz Łożyński for due performance of his duties hereby decides to discharge Mr Mariusz Łożyński, Board member, for due performance of his duties in Resolution no. 11 on discharging Mr. Maciej Bednarkiewicz for due performance of his duties hereby decides to discharge Mr Maciej Bednarkiewicz, Chairman of the Supervisory Board, for due performance of his duties in Resolution no. 12 on discharging Mr. Wiesław Lindner for due performance of his duties hereby decides to discharge Mr Wiesław Lindner, Vice Chairman of the Supervisory Board, for due performance of his duties in Resolution no. 13 on discharging Mr. Jacek Krzyżaniak for due performance of his duties hereby decides to discharge Mr Jacek Krzyżaniak, Member and Secretary of the Supervisory Board, for due performance of his duties in /8
5 Resolution no. 14 on discharging Mr. Dariusz Sarnowski for due performance of his duties hereby decides to discharge Mr Dariusz Sarnowski, member of the Supervisory Board, for due performance of his duties in Resolution no. 15 on discharging Mr. Adam Strzelecki for due performance of his duties hereby decides to discharge Mr Adam Strzelecki, member of the Supervisory Board, for due performance of his duties in Resolution no. 16 on discharging Mr. Mirosław Dobrut for due performance of his duties hereby decides to discharge Mr Mirosław Dobrut, member of the Supervisory Board, for due performance of his duties in Resolution no. 17 on discharging Ms. Małgorzata Wiśniewska for due performance of her duties 5/8
6 hereby decides to discharge Ms Małgorzata Wiśniewska, Member of the Supervisory Board, for due performance of her duties in Resolution no. 18 on the establishment of the number of Supervisory Board Members Pursuant to Art. 29 item 2 the Articles of Association the General Meeting of Shareholders of PBG S.A. hereby decides that the Supervisory Board of the third term shall be composed of 8 (say: eight) members. Resolution no. 19 on appointing Supervisory Board Members Pursuant to Art. 28 item 8 of the Company s Articles of Association, the Annual General Meeting of Shareholders of PBG S.A. hereby appoints the following members of the Supervisory Board of PBG S.A.: - Bednarkiewicz Maciej - Dobrut Mirosław - Krzyżaniak Jacek - Kseń Jacek - Lindner Wiesław - Sarnowski Dariusz - Strzelecki Adam - Wiśniewska Małgorzata Resolution no. 20 on amendments to the Company s Articles of Association 6/8
7 Pursuant to provisions of Article 430 of the Code of Commercial Companies, the General Meeting of Shareholders of PBG S.A. hereby amends the Articles of Associations as follows: 1.Art. 10 item 1 shall read: 4,500,000 series A registered shares, 1,200,000 series A bearer shares. 2.Art. 11 item 2 shall read: The Company founders named in Art. 8 of the Company s Articles of Association holding series A shares shall have the pre-emptive right to acquire series A shares. 3.Art. 14 item 1 shall read: Each series A registered share carries 2 votes. 4.Art. 14 item 3 shall read: Preference as to vote expires upon the disposal of series A shares, unless the purchase is made by the hitherto shareholder who exercises the pre-emptive right mentioned in Art. 11 item 2 of the Articles of Association (in such case, the preference remains in effect). Preference as to vote also remains in force, when series A shares disposed by the hitherto shareholder who exercises the pre-emptive right mentioned in Art. 11 Item 2 of the Articles of Association, will be acquired by an entity, in which the abovementioned party disposing of series A shares is exclusively competent to manage the affaires of the said entity or a right to appoint the bodies of this entity and their members (particularly, the Board of Directors). Resolution no. 21 on authorising the Supervisory Board to prepare a consolidated text of the Company s Articles of Association Pursuant to provisions of Article 430 item 5 of the Code of Commercial Companies, the General Meeting of Shareholders of PBG S.A. hereby authorises the Supervisory Board to prepare a consolidated text of the Company s Articles of Association with the amendments adopted today by the Annual General Meeting of Shareholders. INFORMATION ON OBJECTIONS AGAINST THE RESOLUTIONS SUBJECT TO VOTING: After voting through Resolution no. 20, representative of ING Nationale Nederlanden Polska OFE, Mr. Paweł Szczepański objected to the said resolution. 7/8
8 Legal basis: Art. 39 item 1.5 of the Regulation of 19th October 2005 on current and interim information provided by issuers of securities. Signature of the authorised person: Magdalena Eckert-Boruta 8/8
Raport bieżący nr 13/2016 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016 r.
Nr 13/2016 30 czerwca 2016 r., Poznań Raport przekazywany zgodnie z: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook Data przekazania raportu: 30 czerwca 2016 r. Nazwa emitenta: Carpathia Capital S.A. Siedziba:
RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006
RESOLUTION no. 1/2006 concerning the election of the Chairman In acting pursuant to art. 409 of the Companies Code, the Ordinary General Meeting elects Gabriel Wujek the Chairman of the Meeting. RESOLUTION
statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000;
Uchwała nr 2 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Resolution No. 2 on the assessment of
UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company
UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
RESOLUTION NO... OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA. dated 13 June 2008
regarding the election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Pursuant to Article 409 sentence 1 of the Commercial Companies Code in conjunction with 5 of the Regulations
At the request of shareholder OGM s Agenda was amended by change of p. 9j) and addition of p.9k)
Subject: Amendments in Agenda of Ordinary General Meeting of Pfleiderer Grajewo S.A., to be held on June 29, 2016 at the request of the Company s shareholder Current Report 40/2016 The Management Board
Uchwała nr 04/05/2017. Resolution no 04/05/2017. Rady Nadzorczej Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 maja 2017 roku
Uchwała nr 04/05/2017 Rady Nadzorczej Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia i przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Capital Park S.A. sprawozdania
RB 8/2014 Extraordinary General Meeting of BOŚ S.A. resolutions of 13 March released 13 March 2014
RB 8/2014 Extraordinary General Meeting of BOŚ S.A. resolutions of 13 March 2014. released 13 March 2014 In fulfilment of provisions of 38 subpara. 1 point 7 of the Regulation of the Minister of Finance
No. 2/2017. Poznań, 30 czerwca 2017 r.
Nr 2/2017 No. 2/2017 Poznań, 30 czerwca 2017 r. Poznan, June 30, 2017 Raport przekazywany zgodnie z: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook Data przekazania raportu: 30 czerwca 2017 r. Nazwa emitenta: Carpathia
(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/
Form for exercise voting rights by a proxy at the Annual General Meeting Shareholders ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., convened for 2 May 2016 (place, date) Data the Shareholder Data the
31 December 2017 reflecting other total net income of PLN 5,249,000;
Uchwała nr 2 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Resolution No. 2 on the assessment of
RB 40/2016. Na wniosek akcjonariusza zmieniony został porządek obrad ZWZA poprzez zmianę brzmienia pkt 9j) oraz poprzez dodanie pkt 9k).
Temat: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku na wniosek akcjonariusza RB 40/2016 Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer
Current Report No. 14/2012 Wysogotowo, March 16th 2012
Current Report No. 14/2012 Wysogotowo, March 16th 2012 Subject: Notification of decrease in Pioneer Pekao Investment Management S.A. s holding of PBG shares The Management Board of hereby reports that
26 września 2019 r. 26 September Accor S.A. 82 Rue Henri Farman, Issy-les-Moulineaux Francja. Accor S.A. 82 Rue Henri Farman, France
26 września 2019 r. 26 September 2019 Od: Accor S.A. 82 Rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux Francja Do: Orbis S.A. ul. Złota 59 00-120 Warszawa Polska ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA W PRZEDMIOCIE DODANIA
Beata Maciąg Board Member Grzegorz Latała - Board Member
MERGER PLAN of Mayland Real Estate limited liability company with its registered office in Warsaw and Espace Gdańsk limited liability company with its registered office in Warsaw Pursuant to the provisions
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013. Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013 Data sporządzenia: 2013-05-17 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders - Proposals of Resolutions Podstawa
Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanemu na dzień 28 czerwca 2017 r.
Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanemu na dzień 28 czerwca 2017 r. ABC Data S.A. w dniu 21 marca 2017 r. opublikowała raport roczny nr R 2016 zawierający m.in.:
UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company
UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
Current Report no. 27/2019
Subject: Notification regarding the acquisition of the shares in the share capital of Pfleiderer Group S.A. and the corresponding number of votes at the General Meeting of Shareholders of Pfleiderer Group
Pruszków, 15 marca 2019 r. / Pruszków, March 15, 2019
Pruszków, 15 marca 2019 r. / Pruszków, March 15, 2019 Oświadczenie Rady Nadzorczej Statement of the Supervisory Board Rada Nadzorcza spółki MLP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, pod adresem:
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 32/2013
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 32/2013 Data sporządzenia: 2013-05-31 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Annual General Meeting of Shareholders - Proposals of Resolutions including
Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. ( Spółka ) z dnia 21 czerwca 2017 r. KSH Akcje Program
ZAŁĄCZNIK 1 projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu wraz z wersją porównawczą Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego
Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals
Resolution No.. of the Ordinary General Meeting of the Company Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. dated 30 th May 2014
Draft Resolution No.. of the Ordinary General Meeting of the Company Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. dated 30 th May 2014 on the election of the Chairperson of the Ordinary General Meeting BGŻ S.A. The
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
w sprawie wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Pan/Pani. Uchwała wchodzi w życie
Warszawa, dnia 4 marca 2019 r. Warsaw, March 4 th, Oświadczenie Rady Nadzorczej. Statement of the Supervisory Board
Warszawa, dnia 4 marca 2019 r. Warsaw, March 4 th, 2019 Oświadczenie Rady Nadzorczej Statement of the Supervisory Board Rada Nadzorcza spółki Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem:
The Extraordinary General Meeting of Shareholders hereby adopts the agenda in the following
Resolution no. 1 regarding the election of the Chairman of the General Meeting The Extraordinary General Meeting of Shareholders, acting in accordance with Article 409 1 of the Code of Commercial Companies
Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanemu na dzień 17 maja 2016 r.
Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanemu na dzień 17 maja 2016 r. ABC Data S.A. w dniu 17 marca 2016 r. opublikowała raport roczny nr R 2015 zawierający m.in.:
PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF
PLAN POŁĄCZENIA INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. and INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O *** 30 czerwca 2017 r. / June 3Oth,
Current Report no. 35/2019
Subject: Notice on execution of an agreement of shareholders of Pfleiderer Group S.A. and on exceeding by the parties of the agreement a threshold referred to in article 69 of the public offering act Current
d) review and approval of the annual financial statements of ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny
Resolution no. 1 regarding the election of the Chairman of the General Meeting The Extraordinary General Meeting of Shareholders, acting in accordance with Article 409 1 of the Code of Commercial Companies
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANNOUNCEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING CONVENING
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANNOUNCEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING CONVENING Zarząd Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15a, wpisanej
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z siedzibą w Warszawie
FORMULARZ. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona S.A. z siedzibą w Warszawie
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z siedzibą w Warszawie
Current Report 16/2018
Subject: Request to amend the agenda of Ordinary General Meeting of Pfleiderer Group S.A., to be held on June 11, 2018 and place certain issues on such agenda, submitted by Company s shareholder. Current
Draft resolutions for the Extraordinary General Meeting of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna convened for 21 April 2015
Draft resolutions for the Extraordinary General Meeting of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna convened for 21 April 2015 Re item 2 of the agenda: Resolution no. [ ] regarding the
Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A.
Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Current Report no. 04/2017 The Management Board of Pfleiderer Group S.A. ( Company ) hereby announces that
Warszawa, dnia 5 maja 2014 r.
Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanemu na dzień 23 czerwca 2014 r. ABC Data S.A. w dniu 17 marca 2014 r. opublikowała raport roczny nr R 2013 zawierający m.in.:
Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland
ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia:
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia: 2014-05-16 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 17, 2014 - Proposals of Resolutions
Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:
Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty
UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company
UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 14/2015 Data sporządzenia: 2015%05%15
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 14/2015 Data sporządzenia: 2015%05%15 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 % Proposals of Resolutions
Draft resolutions for the Extraordinary General Meeting of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna convened for 2 May 2016
Draft resolutions for the Extraordinary General Meeting of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna convened for 2 May 2016 Re item 2 of the agenda: Resolution no. [ ] regarding the election
Jason Clarke. date of its adoption. In favour: 7 Against: 0 Abstained: 0. Za: 7 Przeciw: 0 Wstrzymujący się: 0. Dr Michael F.
Uchwała nr 02/05/2017 Rady Nadzorczej Pfleiderer Group S.A. z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania złożonego przez Zarząd projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza Pfleiderer
DRAFT RESOLUTIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GETIN NOBLE BANK S.A.
DRAFT RESOLUTIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GETIN NOBLE BANK S.A. Resolution No. I/09/10/2014 on election of the Chairperson of the General Meeting 1. On the basis of Article 409 1 of the
AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Board of Directors of the Automotive Components Europe S.A. is convening the Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday 21 st of June 2011 at the registered office of the Company at 11am
FORMULARZ. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona S.A. z siedzibą w Warszawie
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z siedzibą w Warszawie
FORMULARZ. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona S.A. z siedzibą w Warszawie
Form for the exercise of the right to vote by attorney-in-fact and for the exercise of the right to vote by correspondence at the Extrardinary FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
1. OTWARCIE OBRAD ORAZ OGŁOSZENIA; WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ORAZ PROTOKOLANTA OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGM) HELD, 11 th JULY 2014 The Annual General ( the General ) of PHOTON ENERGY N.V., with its registered address at Barbara Strozzilaan 201, 1083
KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information
PRELIMINARY RESOLUTIONS
The Management Committee of Automotive Components Europe S.A. herby informs about resolutions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders held at the registered office of the Company, 38, boulevard
CARPATHIA CAPITAL S.A. Krasińskiego 16, Poznań, Poland T:
Nr 7/2015 Poznań, 15 października 2015 r. No 7/2015 Poznań, October 15, 2015 Raport przekazywany zgodnie z: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook Data przekazania raportu: 15 października 2015 r. Nazwa
Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (ze zm. Dz.U. Nr 94, poz. 1037) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (as amended: J.L. No. 94, item 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia
In favor: 7 Against: 0 Abstained: 0
Resolution No. 07/05/2017 of the Supervisory Board of Pfleiderer Group S.A. with its seat in Wrocław dated 25 May 2017 on the approval of the terms of the treasury share repurchase programme presented
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R. W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia
Raport bieżący: 44/2018 Data: g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc
Raport bieżący: 44/2018 Data: 2018-05-23 g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc Temat: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc Podstawa prawna: Inne
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R. W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia
ATLANTIS SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ATLANTIS SE PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ATLANTIS SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding : Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Time of : 2 September 2019, starting at 12.00 (Warsaw Time). Pursuant
POWER OF ATTORNEY TO PARTICIPATE IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA. HELD ON SEPTEMBER 16, 2014
POWER OF ATTORNEY TO PARTICIPATE IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA. HELD ON SEPTEMBER 16, 2014 I, the undersigned *, [name and surname], holding identity card no., domiciled
Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland
ZAWIADOMIENIE O NABYCIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. DAJĄCYCH
Draft Resolutions of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Convened for April 28th 2008
Draft Resolutions Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Convened for April 28th 2008 The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ( PGNiG ) hereby releases the draft resolutions
SYMBIO POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za okres od do roku
SYMBIO POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku Warszawa dn. 26.06.2014 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SYMBIO POLSKA S.A. oraz z badania
Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warsaw, 31 March 2017 The Management Board of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Uchwała nr 595/7/2011 Resolution No. 595/7/2011
Opinia Rady Nadzorczej odnośnie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na 17 czerwca 2011 r. Opinion of the regarding draft resolutions of the Ordinary General Shareholders
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011
Regulamin Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń dostępny jest na stronach internetowych Banku
Sprawozdanie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2017 Komitet jest stałym ciałem doradczym Rady Nadzorczej. W skład Komitetu wchodzi, co najmniej
Current Report 49/2017
Subject: Request to amend the agenda of Extraordinary General Meeting of Pfleiderer Group S.A., to be held on October 18, 2017 and place certain issues on such agenda submitted by Company s shareholder
Raport bieżący nr 16 / 2009
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16 / 2009 Data sporządzenia: 2009-06-10 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Zwołanie i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa
Dokumentacja przedstawiana Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanemu na dzień 21 października 2015 r.
Dokumentacja przedstawiana Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanemu na dzień 21 października 2015 r. Uchwała nr 50/2015 z dnia 17 września 2015 r. Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z siedzibą
No. 17/2018. Poznań, 26 July 2018 r.
Nr 17/2018 No. 17/2018 Poznań, 26 July 2018 r. Poznan, July 26, 2018 Raport przekazywany zgodnie z: Bucharest Stock Exchange ATS Rulebook Data przekazania raportu: 26 lipca 2018 r. Nazwa emitenta: Carpathia
2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, c) Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Echo Investment S.A. i jej Grupy za 2018 rok
OCENA RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT S.A. WRAZ Z UZASADNIENIEM DOTYCZĄCA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ECHO INVESTMENT S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ ECHO INVESTMENT ZA ROK
POLITYKA I PROCEDURA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ ORAZ POLITYKA ŚWIADCZENIA DODATKOWYCH USŁUG PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ LUB PODMIOT POWIĄZANY Z TĄ FIRMĄ
POLICY AND PROCEDURE OF SELECTION OF THE AUDIT FIRM AND POLICY REGARDING PERFORMANCE OF ALLOWED SERVICES BY THE AUDIT FIRM OR AFFILIATES OF SUCH FIRM Considering that Company is a public interest entity
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 27/2013. Temat The Annual General Meeting of Shareholders - Convening Notice
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 27/2013 Data sporządzenia: 2013-05-17 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders - Convening Notice Podstawa prawna
April 26, :00 PM
ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW April 26, 2017 7:00 PM St. Casimir s Parish Hall 154 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario 26 kwietnia 2017 r. godz. 19:00 Audytorium parafii św.
Resolution No... of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna, dated...
Draft Resolutions of the Extraordinary eneral Shareholders Meeting of Polskie órnictwo Naftowe i azownictwo Spółka Akcyjna Convened for November 3rd 2006 Current Report No. 72/2006 of October 16th 2006
OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANNOUNCEMENT OF THE MANAGEMENT BOARD OF CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA OF THE CONVENING OF THE ORDINARY
POWER OF ATTORNEY TO PARTICIPATE IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA. HELD ON DECEMBER 21, 2015
POWER OF ATTORNEY TO PARTICIPATE IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA. HELD ON DECEMBER 21, 2015 I, the undersigned / We, the undersigned *, Name and surname: acting for
Current Report 23/2019
Subject: Request to add additional items the agenda of Ordinary General Meeting of Pfleiderer Group S.A., to be held on June 11, 2019, submitted by Company s shareholder. Current Report 23/2019 The Management
Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (consolidated text J.L. of 2013, item 1030 as
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANNOUNCEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING CONVENING
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANNOUNCEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING CONVENING Zarząd Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15A, wpisanej
ANNOUNCEMENT OF THE MANAGEMENT BOARD OF CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA OF THE CONVENING OF THE ORDINARY GENERAL MEETING
OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANNOUNCEMENT OF THE MANAGEMENT BOARD OF CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA OF THE CONVENING OF THE ORDINARY
25 kwietnia 2018 r. godz. 19:30
ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW April 25, 2018 7:30 PM St. Casimir s Parish Hall 154 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario 25 kwietnia 2018 r. godz. 19:30 Audytorium parafii św.
CARPATHIA CAPITAL S.A. Krasińskiego 16, Poznań T: E:
OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANNOUNCEMENT OF THE MANAGEMENT BOARD OF CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA OF THE CONVENING OF THE ORDINARY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.
W ramach pkt 2 porządku obrad: Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera
Wykaz Raportów. Raporty bieżące. Tytuł raportu. Data przekazania. raportu
Wykaz Raportów Raporty bieżące Lp. Nr raportu Data przekazania Tytuł raportu 1 1/2012 12.01.2012 Oddalenie powództwa o uchylenie uchwały Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 kwietnia
UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company
UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
The date, time, and location of the OGM as well as the detailed agenda
ANNOUNCEMENT OF THE MANAGEMENT BOARD OF ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA WITH ITS REGISTERED OFFICE IN WARSAW REGARDING CONVENING THE ORDINARY GENERAL MEETING OF ROBYG S.A. The Management Board of ROBYG S.A., a company
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016
Raport bieżący nr 16 / 2017
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16 / 2017 Data sporządzenia: 2017-04-26 Skrócona nazwa emitenta Temat Zawiadomienia o liczbie akcji nabytych w wezwaniu ogłoszonym przez Unilin Poland sp.
AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of Automotive Components Europe S.A. is convening the Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday 16 th of June, 2015 at the registered office of the Company at
SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION
SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property
April 21, :00 PM St. Casimir s Parish Hall 154 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario
ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW April 21, 2016 7:00 PM St. Casimir s Parish Hall 154 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario 21 kwietnia 2016 r. godz. 19:00 Audytorium parafii św.
SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION
SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property
MERGER PLAN. for Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. and Rabobank Polska S.A.
MERGER PLAN for Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. and Rabobank Polska S.A. TABLE OF CONTENTS Clause Page DEFINITIONS USED IN THE MERGER PLAN... 1 1. INTRODUCTION... 3 2. NAME, LEGAL FORM AND REGISTERED
1. 13 section 1 of the Articles of Association shall read as follows: ust. 1 Statutu otrzymuje nast puj ce brzmienie:
UCHWAŁA NR [ ]/[ ]/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB W WARSZAWIE ( SPÓŁKA ) Z DNIA [ ] 2019 R. W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI RESOLUTION NO. [ ]/[ ]/2019
PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH: MERGER PLAN FOR CAPITAL COMPANIES: INOUTIC/ DECEUNINCK SP. Z O.O. i PROFIL SYSTEM SP. Z O.O.
PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH: MERGER PLAN FOR CAPITAL COMPANIES: INOUTIC/ DECEUNINCK SP. Z O.O. i PROFIL SYSTEM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI INOUTIC/ DECEUNINCK SP. Z O.O. AND PROFIL SYSTEM SP. Z O.O.